Journal of Korea Technical Association of The Pulp and Paper Industry
/
v.38
no.3
s.116
/
pp.7-12
/
2006
The pore structure of paper was modified by the application of the blending of pulp, refining, and filler particle size and ash content. It was conformed that the reflectivity of paper can be modified by the combination of the above parameters. It was also found that the change of reflectivity of paper was greatly dependent on the pore structure, such as average pore size, pore size distribution and porosity. The average pore size was decreased with addition of HwBKP, but the smallest average pore size was obtained from the addition of 80% HwBKP Refining of pulp decreased both average pore size and the reflectivity of paper. The pore size distribution of filled paper can be varied by the combination of filler particle size and ash content
This paper considers a unrelated parallel machine scheduling problem with ready times, due times and sequence and machine-dependent setup times. The objective of this problem is to determine the allocation of jobs and the scheduling of machines to minimize the total tardy time. A mathematical model for optimal solution is derived. An in-depth analysis of the model shows that it is very complicated and difficult to obtain optimal solutions as the problem size becomes large. Therefore, a genetic algorithm using an effective dispatching method is proposed. The performance of the proposed genetic algorithm is evaluated using several randomly generated examples.
Tohidi, H.;Hosseini-Hashemi, S.H.;Maghsoudpour, A.
Smart Structures and Systems
/
v.22
no.5
/
pp.527-546
/
2018
This article presents an analysis into the nonlinear forced vibration of a micro cylindrical shell reinforced by carbon nanotubes (CNTs) with considering agglomeration effects. The structure is subjected to magnetic field and transverse harmonic mechanical load. Mindlin theory is employed to model the structure and the strain gradient theory (SGT) is also used to capture the size effect. Mori-Tanaka approach is used to estimate the equivalent material properties of the nanocomposite cylindrical shell and consider the CNTs agglomeration effect. The motion equations are derived using Hamilton's principle and the differential quadrature method (DQM) is employed to solve them for obtaining nonlinear frequency response of the cylindrical shells. The effect of different parameters including magnetic field, CNTs volume percent and agglomeration effect, boundary conditions, size effect and length to thickness ratio on the nonlinear forced vibrational characteristic of the of the system is studied. Numerical results indicate that by enhancing the CNTs volume percent, the amplitude of system decreases while considering the CNTs agglomeration effect has an inverse effect.
Objectives This study aims to evaluate the size-dependent toxicity of spherical silver nanoparticles (Ag NPs) to an endemic benthic organism, Glyptotendipes tokunagai. Methods Ag nanoparticles of three nominal sizes (50, 100, and 150 nm) capped with polyvinyl pyrrolidone (PVP-Ag NPs) were used. Their physicochemical properties, acute toxicity (48 hours), and bioaccumulation were measured using third instar larvae of G. tokunagai. Results The aggregation and dissolution of PVP-Ag NPs increased with exposure time and concentration, respectively, particularly for 50 nm PVP-Ag NPs. However, the dissolved concentration of Ag ions was not significant compared with the median lethal concentration value for $AgNO_3$ (3.51 mg/L). The acute toxicity of PVP-Ag NPs was highest for the smallest particles (50 nm), whereas bioaccumulation was greatest for the largest particles (150 nm). However, larger PVP-Ag NPs were absorbed and excreted rapidly, resulting in shorter stays in G. tokunagai than the smaller ones. Conclusions The size of PVP-Ag NPs significantly affects their acute toxicity to G. tokunagai. In particular, smaller PVP-Ag NPs have a higher solubility and stay longer in the body of G. tokunagai, resulting in higher toxicity than larger PVP-Ag NPs.
In the present study, thermo-electro-mechanical vibration characteristics of functionally graded piezoelectric (FGP) Timoshenko nanobeams subjected to in-plane thermal loads and applied electric voltage are carried out by presenting a Navier type solution for the first time. Three kinds of thermal loading, namely, uniform, linear and non-linear temperature rises through the thickness direction are considered. Thermo-electro-mechanical properties of FGP nanobeam are supposed to vary smoothly and continuously throughout the thickness based on power-law model. Eringen's nonlocal elasticity theory is exploited to describe the size dependency of nanobeam. Using Hamilton's principle, the nonlocal equations of motion together with corresponding boundary conditions based on Timoshenko beam theory are obtained for the free vibration analysis of graded piezoelectric nanobeams including size effect and they are solved applying analytical solution. According to the numerical results, it is revealed that the proposed modeling can provide accurate frequency results of the FGP nanobeams as compared to some cases in the literature. In following a parametric study is accompanied to examine the effects of several parameters such as various temperature distributions, external electric voltage, power-law index, nonlocal parameter and mode number on the natural frequencies of the size-dependent FGP nanobeams in detail. It is found that the small scale effect and thermo-electrical loading have a significant effect on natural frequencies of FGP nanobeams.
In this paper, a new size-dependent quasi-3D plate theory is presented for wave dispersion analysis of functionally graded nanoplates while resting on an elastic foundation and under the hygrothermaal environment. This quasi-3D plate theory considers both thickness stretching influences and shear deformation with the variations of displacements in the thickness direction as a parabolic function. Moreover, the stress-free boundary conditions on both sides of the plate are satisfied without using a shear correction factor. This theory includes five independent unknowns with results in only five governing equations. Size effects are obtained via a higher-order nonlocal strain gradient theory of elasticity. A variational approach is adopted to owning the governing equations employing Hamilton's principle. Solving analytically via Fourier series, these equations gives wave frequencies and phase velocities as a function of wave numbers. The validity of the present results is examined by comparing them with those of the known data in the literature. Parametric studies are conducted for material composition, size dependency, two parametric elastic foundation, temperature and moisture differences, and wave number. Some conclusions are drawn from the parametric studies with respect to the wave characteristics.
Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers A
/
v.38
no.3
/
pp.275-282
/
2014
Particle-reinforced metal matrix composites exhibit a strengthening effect due to the particle size-dependent length scale that arises from the strain gradient, and thus from the geometrically necessary dislocations between the particles and matrix that result from their CTE(Coefficient of Thermal Expansion) and elastic-plastic mismatches. In this study, the influence of the size-dependent length scale on the particle-matrix interface failure and ductile failure in the matrix was examined using finite-element punch zone modeling whereby an augmented strength was assigned around the particle. The failure behavior was observed by a parametric study, while varying the interface failure properties such as the interface strength and debonding energy with different particle sizes and volume fractions. It is shown that the two failure modes (interface failure and ductile failure in the matrix) interact with each other and are closely related to the particle size-dependent length scale; in other words, the composite with the smaller particles, which is surrounded by a denser dislocation than that with the larger particles, retards the initiation and growth of the interface and matrix failures, and also leads to a smaller amount of decrease in the flow stress during failure.
Microforming is a very efficient and economical technology to fabricate very small metallic parts in various applications. In order to extend the use of this forming technology for the production of microparts, the size effect, which occurs with the reduction of part size and affects the forming process significantly, must be thoroughly investigated. In this study, the tribological size effect in microforming was studied using modeling and scaled ring compression experiments. A micro-scale friction approach based on the slip-line field theory and lubricant pocket model was used to understand the friction mechanism and explain the tribological size effect. Ring compression tests were performed to analyze the interfacial friction condition from the deformation characteristics of the ring specimens. In addition, finite element analysis results were utilized to quantitatively determine the size-dependent frictional behavior of materials in various process conditions. By comparing theoretical results and experimental measurements for different size factors, the accuracy and reliability of the model were verified.
Kang, Aeyeon;Park, Dae Keun;Hyun, Sang Hwa;Yun, Wan Soo
Proceedings of the Korean Vacuum Society Conference
/
2013.08a
/
pp.267.2-267.2
/
2013
In the citrate reduction method of gold nanoparticle (AuNP) synthesis, pH of the reaction mixture can have a considerable impact on the size and size distribution of AuNPs. In this work, effects of pH variation upon the size and its distribution were examined systematically. As the initial pH was change from 5.5 to 10.5, it showed an optimal pH around 7.5. At this pH, both of the size and the size distribution showed their minimum values, which was verified by transmission electron microscopy and UV-vis spectroscopy. This occurrence of optimal pH was discussed with the results of in situ monitoring pH during the reaction of AuNP synthesis.
Kim, Hyun-Jung;Jeong, Young-Il;Kim, Sung-Ho;Lee, Young-Moo;Cho, Chong-Su
Archives of Pharmacal Research
/
v.20
no.4
/
pp.324-329
/
1997
AB-type amphiphilic copolymers (abbreviated as LE) composed of poly (L-leucine) (PLL) as the A component and poly (ethylene oxide) (PEO) as the B component were synthesized by the ring-opening polymerization of L-leucine N-carboxy-anhydride initiated by methoxy polyoxyethylene amine $(Me-PEO-NH_2)$ and characterized. Core-shell type nanoparticles were prepared by the diafiltration method. Particle size distribution obtained by dynamic light scattering was dependent on PLL composition and the size for LE-1, LE-2 and LE-3 was $369.6{\pm}267$, $523.4{\pm}410$ and $561.2{\pm}364 nm$, respectively. Shapes of the nanoparticies observed by transmission electron microscope (TEM) were almostly spherical. The critical micelle concentration (CMC) of the nanoparticles determined by a fluorescence probe technique was dependent on the composition of hydrophobic PLL, and the CMC for LE-1, LE-2 and LE-3 was $2.0{\times}10^{-6},1.7{\times}10^{-6}$ and $1.5{\times}10^{-6}(mol/l) $, respectively. Clonazepam release from core-shell type nanoparticles in vitro was dependent on PLL composition and drug loading content.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나
그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
[게시일 2004년 10월 1일]
이용약관
제 1 장 총칙
제 1 조 (목적)
이 이용약관은 KoreaScience 홈페이지(이하 “당 사이트”)에서 제공하는 인터넷 서비스(이하 '서비스')의 가입조건 및 이용에 관한 제반 사항과 기타 필요한 사항을 구체적으로 규정함을 목적으로 합니다.
제 2 조 (용어의 정의)
① "이용자"라 함은 당 사이트에 접속하여 이 약관에 따라 당 사이트가 제공하는 서비스를 받는 회원 및 비회원을
말합니다.
② "회원"이라 함은 서비스를 이용하기 위하여 당 사이트에 개인정보를 제공하여 아이디(ID)와 비밀번호를 부여
받은 자를 말합니다.
③ "회원 아이디(ID)"라 함은 회원의 식별 및 서비스 이용을 위하여 자신이 선정한 문자 및 숫자의 조합을
말합니다.
④ "비밀번호(패스워드)"라 함은 회원이 자신의 비밀보호를 위하여 선정한 문자 및 숫자의 조합을 말합니다.
제 3 조 (이용약관의 효력 및 변경)
① 이 약관은 당 사이트에 게시하거나 기타의 방법으로 회원에게 공지함으로써 효력이 발생합니다.
② 당 사이트는 이 약관을 개정할 경우에 적용일자 및 개정사유를 명시하여 현행 약관과 함께 당 사이트의
초기화면에 그 적용일자 7일 이전부터 적용일자 전일까지 공지합니다. 다만, 회원에게 불리하게 약관내용을
변경하는 경우에는 최소한 30일 이상의 사전 유예기간을 두고 공지합니다. 이 경우 당 사이트는 개정 전
내용과 개정 후 내용을 명확하게 비교하여 이용자가 알기 쉽도록 표시합니다.
제 4 조(약관 외 준칙)
① 이 약관은 당 사이트가 제공하는 서비스에 관한 이용안내와 함께 적용됩니다.
② 이 약관에 명시되지 아니한 사항은 관계법령의 규정이 적용됩니다.
제 2 장 이용계약의 체결
제 5 조 (이용계약의 성립 등)
① 이용계약은 이용고객이 당 사이트가 정한 약관에 「동의합니다」를 선택하고, 당 사이트가 정한
온라인신청양식을 작성하여 서비스 이용을 신청한 후, 당 사이트가 이를 승낙함으로써 성립합니다.
② 제1항의 승낙은 당 사이트가 제공하는 과학기술정보검색, 맞춤정보, 서지정보 등 다른 서비스의 이용승낙을
포함합니다.
제 6 조 (회원가입)
서비스를 이용하고자 하는 고객은 당 사이트에서 정한 회원가입양식에 개인정보를 기재하여 가입을 하여야 합니다.
제 7 조 (개인정보의 보호 및 사용)
당 사이트는 관계법령이 정하는 바에 따라 회원 등록정보를 포함한 회원의 개인정보를 보호하기 위해 노력합니다. 회원 개인정보의 보호 및 사용에 대해서는 관련법령 및 당 사이트의 개인정보 보호정책이 적용됩니다.
제 8 조 (이용 신청의 승낙과 제한)
① 당 사이트는 제6조의 규정에 의한 이용신청고객에 대하여 서비스 이용을 승낙합니다.
② 당 사이트는 아래사항에 해당하는 경우에 대해서 승낙하지 아니 합니다.
- 이용계약 신청서의 내용을 허위로 기재한 경우
- 기타 규정한 제반사항을 위반하며 신청하는 경우
제 9 조 (회원 ID 부여 및 변경 등)
① 당 사이트는 이용고객에 대하여 약관에 정하는 바에 따라 자신이 선정한 회원 ID를 부여합니다.
② 회원 ID는 원칙적으로 변경이 불가하며 부득이한 사유로 인하여 변경 하고자 하는 경우에는 해당 ID를
해지하고 재가입해야 합니다.
③ 기타 회원 개인정보 관리 및 변경 등에 관한 사항은 서비스별 안내에 정하는 바에 의합니다.
제 3 장 계약 당사자의 의무
제 10 조 (KISTI의 의무)
① 당 사이트는 이용고객이 희망한 서비스 제공 개시일에 특별한 사정이 없는 한 서비스를 이용할 수 있도록
하여야 합니다.
② 당 사이트는 개인정보 보호를 위해 보안시스템을 구축하며 개인정보 보호정책을 공시하고 준수합니다.
③ 당 사이트는 회원으로부터 제기되는 의견이나 불만이 정당하다고 객관적으로 인정될 경우에는 적절한 절차를
거쳐 즉시 처리하여야 합니다. 다만, 즉시 처리가 곤란한 경우는 회원에게 그 사유와 처리일정을 통보하여야
합니다.
제 11 조 (회원의 의무)
① 이용자는 회원가입 신청 또는 회원정보 변경 시 실명으로 모든 사항을 사실에 근거하여 작성하여야 하며,
허위 또는 타인의 정보를 등록할 경우 일체의 권리를 주장할 수 없습니다.
② 당 사이트가 관계법령 및 개인정보 보호정책에 의거하여 그 책임을 지는 경우를 제외하고 회원에게 부여된
ID의 비밀번호 관리소홀, 부정사용에 의하여 발생하는 모든 결과에 대한 책임은 회원에게 있습니다.
③ 회원은 당 사이트 및 제 3자의 지적 재산권을 침해해서는 안 됩니다.
제 4 장 서비스의 이용
제 12 조 (서비스 이용 시간)
① 서비스 이용은 당 사이트의 업무상 또는 기술상 특별한 지장이 없는 한 연중무휴, 1일 24시간 운영을
원칙으로 합니다. 단, 당 사이트는 시스템 정기점검, 증설 및 교체를 위해 당 사이트가 정한 날이나 시간에
서비스를 일시 중단할 수 있으며, 예정되어 있는 작업으로 인한 서비스 일시중단은 당 사이트 홈페이지를
통해 사전에 공지합니다.
② 당 사이트는 서비스를 특정범위로 분할하여 각 범위별로 이용가능시간을 별도로 지정할 수 있습니다. 다만
이 경우 그 내용을 공지합니다.
제 13 조 (홈페이지 저작권)
① NDSL에서 제공하는 모든 저작물의 저작권은 원저작자에게 있으며, KISTI는 복제/배포/전송권을 확보하고
있습니다.
② NDSL에서 제공하는 콘텐츠를 상업적 및 기타 영리목적으로 복제/배포/전송할 경우 사전에 KISTI의 허락을
받아야 합니다.
③ NDSL에서 제공하는 콘텐츠를 보도, 비평, 교육, 연구 등을 위하여 정당한 범위 안에서 공정한 관행에
합치되게 인용할 수 있습니다.
④ NDSL에서 제공하는 콘텐츠를 무단 복제, 전송, 배포 기타 저작권법에 위반되는 방법으로 이용할 경우
저작권법 제136조에 따라 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.
제 14 조 (유료서비스)
① 당 사이트 및 협력기관이 정한 유료서비스(원문복사 등)는 별도로 정해진 바에 따르며, 변경사항은 시행 전에
당 사이트 홈페이지를 통하여 회원에게 공지합니다.
② 유료서비스를 이용하려는 회원은 정해진 요금체계에 따라 요금을 납부해야 합니다.
제 5 장 계약 해지 및 이용 제한
제 15 조 (계약 해지)
회원이 이용계약을 해지하고자 하는 때에는 [가입해지] 메뉴를 이용해 직접 해지해야 합니다.
제 16 조 (서비스 이용제한)
① 당 사이트는 회원이 서비스 이용내용에 있어서 본 약관 제 11조 내용을 위반하거나, 다음 각 호에 해당하는
경우 서비스 이용을 제한할 수 있습니다.
- 2년 이상 서비스를 이용한 적이 없는 경우
- 기타 정상적인 서비스 운영에 방해가 될 경우
② 상기 이용제한 규정에 따라 서비스를 이용하는 회원에게 서비스 이용에 대하여 별도 공지 없이 서비스 이용의
일시정지, 이용계약 해지 할 수 있습니다.
제 17 조 (전자우편주소 수집 금지)
회원은 전자우편주소 추출기 등을 이용하여 전자우편주소를 수집 또는 제3자에게 제공할 수 없습니다.
제 6 장 손해배상 및 기타사항
제 18 조 (손해배상)
당 사이트는 무료로 제공되는 서비스와 관련하여 회원에게 어떠한 손해가 발생하더라도 당 사이트가 고의 또는 과실로 인한 손해발생을 제외하고는 이에 대하여 책임을 부담하지 아니합니다.
제 19 조 (관할 법원)
서비스 이용으로 발생한 분쟁에 대해 소송이 제기되는 경우 민사 소송법상의 관할 법원에 제기합니다.
[부 칙]
1. (시행일) 이 약관은 2016년 9월 5일부터 적용되며, 종전 약관은 본 약관으로 대체되며, 개정된 약관의 적용일 이전 가입자도 개정된 약관의 적용을 받습니다.