Park, Su-Jung;Leesungbok, Richard;Ahn, Su-Jin;Im, Byung-Jin;Lee, Do Yun;Jee, Yu-Jin;Yoon, Joon-Ho;Cui, Taixing;Lee, Sang Cheon;Lee, Suk Won
The Journal of Advanced Prosthodontics
/
제7권6호
/
pp.496-505
/
2015
PURPOSE. To determine the effect of fibronectin (FN)-conjugated, microgrooved titanium (Ti) on osteoblast differentiation and gene expression in human bone marrow-derived mesenchymal stem cells (MSCs). MATERIALS AND METHODS. Photolithography was used to fabricate the microgrooved Ti, and amine functionalization (silanization) was used to immobilize fibronectin on the titanium surfaces. Osteoblast differentiation and osteoblast marker gene expression were analyzed by means of alkaline phosphatase activity assay, extracellular calcium deposition assay, and quantitative real-time PCR. RESULTS. The conjugation of fibronectin on Ti significantly increased osteoblast differentiation in MSCs compared with non-conjugated Ti substrates. On the extracellular calcium deposition assays of MSCs at 21 days, an approximately two-fold increase in calcium concentration was observed on the etched 60-${\mu}m$-wide/10-${\mu}m$-deep microgrooved surface with fibronectin (E60/10FN) compared with the same surface without fibronectin (E60/10), and a more than four-fold increase in calcium concentration was observed on E60/10FN compared with the non-etched control (NE0) and etched control (E0) surfaces. Through a series of analyses to determine the expression of osteoblast marker genes, a significant increase in all the marker genes except type I collagen ${\alpha}1$ mRNA was seen with E60/10FN more than with any of the other groups, as compared with NE0. CONCLUSION. The FN-conjugated, microgrooved Ti substrate can provide an effective surface to promote osteoblast differentiation and osteoblast marker gene expression in MSCs.
Background: It is well-known that cell-free nucleic acids rise in patients with many types of malignancies. Several recent experimental studies using cancer cell lines have shown that changes in cell-free RNA are predictive of the response to chemotherapy. The objective of this study was to determine whether quantification of free RNA can be used as a biomarker for clinical responses to chemotherapy in patients with lung cancer. Methods: Thirty-two patients with lung cancer (non-small cell lung cancer, n=24; small cell lung cancer, n=8) were divided into 2 groups according to their responses to chemotherapy (response group, n=19; non-response group, n=13). Blood samples were collected before and after two cycles of chemotherapy. Real-time quantitative RT-PCR was used for transcript quantification of the glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase gene. Results: The pre chemotherapy values (Response group $41.36{\pm}1.72$ vs. Non-response group $41.33{\pm}1.54$, p=0.78) and post chemotherapy values (Response group $39.92{\pm}1.81$ vs. Non-response group $40.41{\pm}1.47$, p=0.40) for cell free RNA concentrations, expressed as Ct GAPDH (threshold cycle glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase gene) levels, was not different between the two groups. There was no significant relationship between changes in the cell free RNA level clinical responses after chemotherapy (p=0.43). Conclusion: We did not find a correlation between quantification of serum cell free RNA levels and clinical responses to chemotherapy in patients with lung cancer. Further investigations are needed to determine whether the cell free RNA level is a useful predictor of responses to chemotherapy in patients with lung cancer.
Transplantation is considered to be a very useful approach to improve human welfare and to prolong life-span. Heterologous organ transplantation using pig organs which are similar to human beings and easy to make mass-production has known as one of the alternatives. To ensure potential usage of the pig organ for transplantation application, it is essentially required to generate transgenic pig modifying immuno-related genes. Previously, we reported production of heterozygous ${\alpha}1,3$-galactosyltransferase (GalT) knock-out and human membrane cofactor protein (MCP) expressing pig ($GalT^{-MCP/+}$), which is enforced for suppression of hyperacute and acute immunological rejection. In this study, we reported generation of homozygous pig ($GalT^{-MCP/-MCP}$) by crossbreeding $GalT^{-MCP/+}$ pigs. Two female founders gave birth to six of $GalT^{-MCP/-MCP}$, and seven $GalT^{-MCP/+}$ pigs. We performed quantitative real-time PCR, western blot, and flow cytometry analyses to confirm GalT and MCP expression. We showed that fibroblasts of the $GalT^{-MCP/-MCP}$ pig do not express GalT and its product Gal antigen, while efficiently express MCP. We also showed no expression of GalT, otherwise expression of MCP at heart, kidney, liver and pancreas of transgenic pig. Taken together, we suggest that the $GalT^{-MCP/-MCP}$ pig is a useful candidate to apply xenotransplantation study.
최근 돼지의 장기를 사람에게 이식하는 이종간 장기 이식에 관한 연구가 급속히 발전되고 있다. 그러나 돼지의 장기를 이식할 경우 가장 큰 문제점 중의 하나는 돼지 genome 내에 존재하는 내인성 레트로바이러스(porcine endogenous retrovirus; PERV)가 인간에게 그대로 전이될 수 있다는 것이다. 이에 대한 대안으로 최근 활발히 연구되고 있는 RNA 간섭을 통한 PERV RNA의 발현을 최대한 억제하는 방법이 제안되고 있는데, RNA 간섭(RNA interference)은 double-standard RNA(dsRNA)가 상보적인 표적 mRNA를 분해하여 결과적으로 표적 단백질의 발현을 특이적으로 억제하는 현상을 의미한다. 본 연구에서는 PERV에 대한 RNA 간섭 현상을 일으키는 shRNA 유전자를 레트로바이러스 벡터를 이용하여 돼지세포에 RNA)가 상보적인 표적 mRNA를 분해하여 결과적으로 표적 단백질의 발현을 특이적으로 억제하는 현상을 의미하다. 도입한 후 PERV의 발현율 감소 여부를 조사하였다. 그 결과, gag-pol 유전자와 env 유전자 발현은 각각 대조군 세포의 4%와 10% 정도로 억제되었다. 한편, virus 입자의 생산에서 gag-pol 유전자는 대조군 세포에 비해 300배 이상 억제되었으며, env 유전자에서는 20만 배 이상 억제되었다. 이상의 결과를 미루어 볼 때 형질 전환 돼지를 이용한 이종 장기 이식에 있어서 RNA 간섭 현상을 이용한 PERV의 발현을 억제하는 시도는 생물학적안전성을 크게 증가시킬 수 있을 것으로 사료된다.
체세포 핵이식을 통한 형질전환 소를 생산 시 초기 수정란 발육 시 발생하는 주요 유전자의 이상 발현을 규명을 목적으로 본 연구를 수행하였다. 형질전환 복제수정란의 낮은 발육능의 원인을 규명하기 위해 하기 위하여 단위 발생란, 체외수정란 및 형질전환 복제수정란에서 초기 배 발육에 중요한 유전자인 IFN-t, Oct4 및 Fgf4유전자의 발현량을 비교 분석하였다. RNA는 각각 10개 수정란에서 추출한 후 reverse-transcription하여 first cDNA를 합성하고 이를 가지고 실시간 중합효수 연쇄반응을 실시하였다. IFN-t유전자의 발현은 형질전환 복제란에서 유의적으로 높게 나왔다 (P<0.05).그러나 Oct4 및 Fgf4 유전자의 경우 형질전환 복제란에서 체외수정란에 비해 유의적으로 낮게 나옴을 확인하였다. 이상의 결과로, 형질전환 복제수정란의 낮은 발육능이 원인이 발육에 중요한 유전자의 이상 발현에 기인된다고 사료된다.
Kim, Minjeong;Yun, Jun-Won;Shin, Kyeho;Cho, Yejin;Yang, Mijeong;Nam, Ki Taek;Lim, Kyung-Min
Biomolecules & Therapeutics
/
제25권2호
/
pp.112-121
/
2017
Drug-induced liver injury (DILI) is the serious and fatal drug-associated adverse effect, but its incidence is very low and individual variation in severity is substantial. Acetaminophen (APAP)-induced liver injury accounts for >50% of reported DILI cases but little is known for the cause of individual variations in the severity. Intrinsic genetic variation is considered a key element but the identity of the genes was not well-established. Here, pre-biopsy method and microarray technique was applied to uncover the key genes for APAP-induced liver injury in mice, and a cause and effect experiment employing quantitative real-time PCR was conducted to confirm the correlation between the uncovered genes and APAP-induced hepatotoxicity. We identified the innately and differentially expressed genes of mice susceptible to APAP-induced hepatotoxicity in the pre-biopsied liver tissue before APAP treatment through microarray analysis of the global gene expression profiles (Affymetrix $GeneChip^{(R)}$ Mouse Gene 1.0 ST for 28,853 genes). Expression of 16 genes including Gdap10, Lpl, Gabra3 and Ccrn4l were significantly different (t-test: FDR <10%) more than 1.5 fold in the susceptible animals than resistant. To confirm the association with the susceptibility to APAP-induced hepatotoxicity, another set of animals were measured for the expression level of selected 4 genes (higher two and lower two genes) in the liver pre-biopsy and their sensitivity to APAP-induced hepatotoxicity was evaluated by post hoc. Notably, the expressions of Gabra3 and Lpl were significantly correlated with the severity of liver injury (p<0.05) demonstrating that these genes may be linked to the susceptibility to APAP-induced hepatotoxicity.
Abiero, Arvie;Ryu, In Soo;Botanas, Chrislean Jun;Custodio, Raly James Perez;Sayson, Leandro Val;Kim, Mikyung;Lee, Hyun Jun;Kim, Hee Jin;Seo, Joung-Wook;Cho, Min Chang;Lee, Kun Won;Yoo, Sung Yeun;Jang, Choon-Gon;Lee, Yong Sup;Cheong, Jae Hoon
Biomolecules & Therapeutics
/
제28권1호
/
pp.83-91
/
2020
Tryptamines are monoamine alkaloids with hallucinogenic properties and are widely abused worldwide. To hasten the regulations of novel substances and predict their abuse potential, we designed and synthesized four novel synthetic tryptamine analogs: Pyrrolidino tryptamine hydrochloride (PYT HCl), Piperidino tryptamine hydrochloride (PIT HCl), N,N-dibutyl tryptamine hydrochloride (DBT HCl), and 2-Methyl tryptamine hydrochloride (2-MT HCl). Then, we evaluated their rewarding and reinforcing effects using the conditioned place preference (CPP) and self-administration (SA) paradigms. We conducted an open field test (OFT) to determine the effects of the novel compounds on locomotor activity. A head-twitch response (HTR) was also performed to characterize their hallucinogenic properties. Lastly, we examined the effects of the compounds on 5-HTR1a and 5-HTR2a in the prefrontal cortex using a quantitative real-time polymerase chain reaction (qRT-PCR) assay. None of the compounds induced CPP in mice or initiated SA in rats. PYT HCl and PIT HCl reduced the locomotor activity and elevated the 5-HTR1a mRNA levels in mice. Acute and repeated treatment with the novel tryptamines elicited HTR in mice. Furthermore, a drug challenge involving a 7-day abstinence from drug use produced higher HTR than acute and repeated treatments. Both the acute treatment and drug challenge increased the 5-HTR2a mRNA levels. Ketanserin blocked the induced HTR. Taken together, the findings suggest that PYT HCl, PIT HCl, DBT HCl, and 2-MT HCl produce hallucinogenic effects via 5-HTR2a stimulation, but may have low abuse potential.
Objective: To understand the crucial requirement for the normal early folliculogenesis, we evaluated molecular as well as physiological differences during in vitro ovarian culture. Among the important regulators for follicle development, anti-Müllerian hormone (AMH) and FSH Receptor (FSHR) have been known to be expressed in the cuboidal granulosa cells. Meanwhile, it is known that c-kit is germ cell-specific and GDF-9 is also oocyte-specific regulator. To evaluate the functional requirement for the competence of normal follicular development, we investigated the differential mRNA expression of several factors secreted from granulosa cells and oocytes between in vivo and in vitro developed ovaries. Materials and Methods: Ovaries from ICR neonates (the day of birth) were cultured for 4 days (for primordial to primary transition) or 8 days (for secondary follicle formation) in ${\alpha}$-MEM glutamax supplemented with 3 mg/ml BSA without serum or growth factors. The mRNA levels of the several factors were investigated by quantitative real-time PCR analysis. Freshly isolated 0-, 4-, and 8-day-old ovaries were used as control. Results: The mRNA of AMH and FSHR as granulosa cell factors was highly increased according to the ovarian development in both of 4- and 8-day-old control. However, the mRNA expression was not induced in both of 4- and 8-day in vitro cultured ovaries. The mRNA expression of GDF-9 known to regulate follicle growth as an oocyte factor was different between in vivo and in vitro developed ovaries. In addition, the transcript of GDF-9 was expressed in the primordial follicles of mouse ovaries. The mRNA expression of c-kit was not significantly different during the early folliculogenesis in vitro. Conclusion: This is the first report regarding endogenous AMH and FSHR expression during the early folliculogenesis in vitro. In conclusion, it will be very valuable to evaluate cuboidal granulosa cell factors as functional marker(s) for normal early folliculogenesis in vitro.
Anabolic steroids are frequently used to increase the growth rate of meat-producing animals. Exposure to an anabolic-androgenic steroid, nandrolone decanoate (ND), is associated with expressional reduction of testicular steroidogenic enzymes. However, the effect of withdrawal of ND exposure on the expression of these testicular molecules has not been thoroughly explored. The current research investigated expression changes of testicular steroidogenic enzymes in rats at several recovery periods (2, 6, and 12 weeks) after the stop of ND treatment with different doses (2 and 10 mg/kg body weight) for 12 weeks. Body and testis weights were recorded, and transcript levels of molecules were determined by quantitative real-time polymerase chain reaction (PCR). The immunohistochemistry was used to examine the changes of immuno-intensities of molecules. At 6 and 12 weeks of the recovery period, the 10 mg/kg ND-treated rats were lighter than other experimental groups. The interstitial compartment vanished by ND treatment filled up as the recovery period became longer. The expression of steroidogenic acute regulatory protein was returned to the control level at 12 weeks of the recovery period. Expression levels of cytochrome P450 side-chain cleavage and 17a-hydroxylase were increased in 2 mg/kg ND-treated group at 6 weeks of the recovery period, and transcript levels of these molecules in 2 and 10 mg/kg ND-treated groups at 12 weeks of the recovery period were significantly lower than the control. Expression levels of 3β-hydroxysteroid dehydrogenase (HSD) type I and 17β-HSD type 3 in 2 mg/kg ND-treated group were comparable with those of control at 12 weeks of the recovery period, but not in 10 mg/kg ND-treated group. Expression of cytochrome P450 aromatase (Cyp19) was reverted to the control level at 2 weeks of the recovery period. Except for Cyp19, there was a visible increase of immuno-staining intensity of other testicular steroidogenic enzymes in the Leydig cells as the recovery period progressed. This research has demonstrated that the cease of ND administration could restore the expression of testicular steroidogenic enzymes close to the normal level. Nevertheless, a relatively long recovery period, compared to the ND-exposure period would be required to retrieve normal expression levels of testicular steroidogenic enzymes.
N-acyl-homoserine lactone quorum sensing (AHL-QS) has been shown to regulate many physiological behaviors in Serratia marcescens MG1. In the current study, the effects of AHL-QS on the biosynthesis of acid and neutral products by S. marcescens MG1 and its isogenic ${\Delta}swrI$ with or without supplementing exogenous N-hexanoyl-L-homoserine lactone ($C_6-HSL$) were systematically investigated. The results showed that swrI disruption resulted in rapid pH drops from 7.0 to 4.8, which could be restored to wild type by supplementing $C_6-HSL$. Furthermore, fermentation product analysis indicated that ${\Delta}swrI$ could lead to obvious accumulation for acidogenesis products such as lactic acid and succinic acid, especially excess acetic acid (2.27 g/l) produced at the early stage of fermentation, whereas solventogenesis products by ${\Delta}swrI$ appeared to noticeably decrease by an approximate 30% for acetoin during 32-48 h and by an approximate 20% for 2,3-butanediol during 24-40 h, when compared to those by wild type. Interestingly, the excess acetic acid produced could be removed in an AHL-QS-independent manner. Subsequently, quantitative real-time PCR was used to determine the mRNA expression levels of genes responsible for acidogenesis and solventogenesis and showed consistent results with those of product synthesis. Finally, by close examination of promoter regions of the analyzed genes, four putative luxI box-like motifs were found upstream of genes encoding acetyl-CoA synthase, lactate dehydrogenase, ${\alpha}$-acetolactate decarboxylase, and Lys-like regulator. The information from this study provides a novel insight into the roles played by AHL-QS in switching from acidogenesis to solventogenesis in S. marcescens MG1.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나
그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
[게시일 2004년 10월 1일]
이용약관
제 1 장 총칙
제 1 조 (목적)
이 이용약관은 KoreaScience 홈페이지(이하 “당 사이트”)에서 제공하는 인터넷 서비스(이하 '서비스')의 가입조건 및 이용에 관한 제반 사항과 기타 필요한 사항을 구체적으로 규정함을 목적으로 합니다.
제 2 조 (용어의 정의)
① "이용자"라 함은 당 사이트에 접속하여 이 약관에 따라 당 사이트가 제공하는 서비스를 받는 회원 및 비회원을
말합니다.
② "회원"이라 함은 서비스를 이용하기 위하여 당 사이트에 개인정보를 제공하여 아이디(ID)와 비밀번호를 부여
받은 자를 말합니다.
③ "회원 아이디(ID)"라 함은 회원의 식별 및 서비스 이용을 위하여 자신이 선정한 문자 및 숫자의 조합을
말합니다.
④ "비밀번호(패스워드)"라 함은 회원이 자신의 비밀보호를 위하여 선정한 문자 및 숫자의 조합을 말합니다.
제 3 조 (이용약관의 효력 및 변경)
① 이 약관은 당 사이트에 게시하거나 기타의 방법으로 회원에게 공지함으로써 효력이 발생합니다.
② 당 사이트는 이 약관을 개정할 경우에 적용일자 및 개정사유를 명시하여 현행 약관과 함께 당 사이트의
초기화면에 그 적용일자 7일 이전부터 적용일자 전일까지 공지합니다. 다만, 회원에게 불리하게 약관내용을
변경하는 경우에는 최소한 30일 이상의 사전 유예기간을 두고 공지합니다. 이 경우 당 사이트는 개정 전
내용과 개정 후 내용을 명확하게 비교하여 이용자가 알기 쉽도록 표시합니다.
제 4 조(약관 외 준칙)
① 이 약관은 당 사이트가 제공하는 서비스에 관한 이용안내와 함께 적용됩니다.
② 이 약관에 명시되지 아니한 사항은 관계법령의 규정이 적용됩니다.
제 2 장 이용계약의 체결
제 5 조 (이용계약의 성립 등)
① 이용계약은 이용고객이 당 사이트가 정한 약관에 「동의합니다」를 선택하고, 당 사이트가 정한
온라인신청양식을 작성하여 서비스 이용을 신청한 후, 당 사이트가 이를 승낙함으로써 성립합니다.
② 제1항의 승낙은 당 사이트가 제공하는 과학기술정보검색, 맞춤정보, 서지정보 등 다른 서비스의 이용승낙을
포함합니다.
제 6 조 (회원가입)
서비스를 이용하고자 하는 고객은 당 사이트에서 정한 회원가입양식에 개인정보를 기재하여 가입을 하여야 합니다.
제 7 조 (개인정보의 보호 및 사용)
당 사이트는 관계법령이 정하는 바에 따라 회원 등록정보를 포함한 회원의 개인정보를 보호하기 위해 노력합니다. 회원 개인정보의 보호 및 사용에 대해서는 관련법령 및 당 사이트의 개인정보 보호정책이 적용됩니다.
제 8 조 (이용 신청의 승낙과 제한)
① 당 사이트는 제6조의 규정에 의한 이용신청고객에 대하여 서비스 이용을 승낙합니다.
② 당 사이트는 아래사항에 해당하는 경우에 대해서 승낙하지 아니 합니다.
- 이용계약 신청서의 내용을 허위로 기재한 경우
- 기타 규정한 제반사항을 위반하며 신청하는 경우
제 9 조 (회원 ID 부여 및 변경 등)
① 당 사이트는 이용고객에 대하여 약관에 정하는 바에 따라 자신이 선정한 회원 ID를 부여합니다.
② 회원 ID는 원칙적으로 변경이 불가하며 부득이한 사유로 인하여 변경 하고자 하는 경우에는 해당 ID를
해지하고 재가입해야 합니다.
③ 기타 회원 개인정보 관리 및 변경 등에 관한 사항은 서비스별 안내에 정하는 바에 의합니다.
제 3 장 계약 당사자의 의무
제 10 조 (KISTI의 의무)
① 당 사이트는 이용고객이 희망한 서비스 제공 개시일에 특별한 사정이 없는 한 서비스를 이용할 수 있도록
하여야 합니다.
② 당 사이트는 개인정보 보호를 위해 보안시스템을 구축하며 개인정보 보호정책을 공시하고 준수합니다.
③ 당 사이트는 회원으로부터 제기되는 의견이나 불만이 정당하다고 객관적으로 인정될 경우에는 적절한 절차를
거쳐 즉시 처리하여야 합니다. 다만, 즉시 처리가 곤란한 경우는 회원에게 그 사유와 처리일정을 통보하여야
합니다.
제 11 조 (회원의 의무)
① 이용자는 회원가입 신청 또는 회원정보 변경 시 실명으로 모든 사항을 사실에 근거하여 작성하여야 하며,
허위 또는 타인의 정보를 등록할 경우 일체의 권리를 주장할 수 없습니다.
② 당 사이트가 관계법령 및 개인정보 보호정책에 의거하여 그 책임을 지는 경우를 제외하고 회원에게 부여된
ID의 비밀번호 관리소홀, 부정사용에 의하여 발생하는 모든 결과에 대한 책임은 회원에게 있습니다.
③ 회원은 당 사이트 및 제 3자의 지적 재산권을 침해해서는 안 됩니다.
제 4 장 서비스의 이용
제 12 조 (서비스 이용 시간)
① 서비스 이용은 당 사이트의 업무상 또는 기술상 특별한 지장이 없는 한 연중무휴, 1일 24시간 운영을
원칙으로 합니다. 단, 당 사이트는 시스템 정기점검, 증설 및 교체를 위해 당 사이트가 정한 날이나 시간에
서비스를 일시 중단할 수 있으며, 예정되어 있는 작업으로 인한 서비스 일시중단은 당 사이트 홈페이지를
통해 사전에 공지합니다.
② 당 사이트는 서비스를 특정범위로 분할하여 각 범위별로 이용가능시간을 별도로 지정할 수 있습니다. 다만
이 경우 그 내용을 공지합니다.
제 13 조 (홈페이지 저작권)
① NDSL에서 제공하는 모든 저작물의 저작권은 원저작자에게 있으며, KISTI는 복제/배포/전송권을 확보하고
있습니다.
② NDSL에서 제공하는 콘텐츠를 상업적 및 기타 영리목적으로 복제/배포/전송할 경우 사전에 KISTI의 허락을
받아야 합니다.
③ NDSL에서 제공하는 콘텐츠를 보도, 비평, 교육, 연구 등을 위하여 정당한 범위 안에서 공정한 관행에
합치되게 인용할 수 있습니다.
④ NDSL에서 제공하는 콘텐츠를 무단 복제, 전송, 배포 기타 저작권법에 위반되는 방법으로 이용할 경우
저작권법 제136조에 따라 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.
제 14 조 (유료서비스)
① 당 사이트 및 협력기관이 정한 유료서비스(원문복사 등)는 별도로 정해진 바에 따르며, 변경사항은 시행 전에
당 사이트 홈페이지를 통하여 회원에게 공지합니다.
② 유료서비스를 이용하려는 회원은 정해진 요금체계에 따라 요금을 납부해야 합니다.
제 5 장 계약 해지 및 이용 제한
제 15 조 (계약 해지)
회원이 이용계약을 해지하고자 하는 때에는 [가입해지] 메뉴를 이용해 직접 해지해야 합니다.
제 16 조 (서비스 이용제한)
① 당 사이트는 회원이 서비스 이용내용에 있어서 본 약관 제 11조 내용을 위반하거나, 다음 각 호에 해당하는
경우 서비스 이용을 제한할 수 있습니다.
- 2년 이상 서비스를 이용한 적이 없는 경우
- 기타 정상적인 서비스 운영에 방해가 될 경우
② 상기 이용제한 규정에 따라 서비스를 이용하는 회원에게 서비스 이용에 대하여 별도 공지 없이 서비스 이용의
일시정지, 이용계약 해지 할 수 있습니다.
제 17 조 (전자우편주소 수집 금지)
회원은 전자우편주소 추출기 등을 이용하여 전자우편주소를 수집 또는 제3자에게 제공할 수 없습니다.
제 6 장 손해배상 및 기타사항
제 18 조 (손해배상)
당 사이트는 무료로 제공되는 서비스와 관련하여 회원에게 어떠한 손해가 발생하더라도 당 사이트가 고의 또는 과실로 인한 손해발생을 제외하고는 이에 대하여 책임을 부담하지 아니합니다.
제 19 조 (관할 법원)
서비스 이용으로 발생한 분쟁에 대해 소송이 제기되는 경우 민사 소송법상의 관할 법원에 제기합니다.
[부 칙]
1. (시행일) 이 약관은 2016년 9월 5일부터 적용되며, 종전 약관은 본 약관으로 대체되며, 개정된 약관의 적용일 이전 가입자도 개정된 약관의 적용을 받습니다.